[1]
Name
Bild
Eintragsdatum
Lage
Ort
Beschreibung
1
Emanuel and Christina Anderson House
Emanuel and Christina Anderson House
22. Mai 2005 ID-Nr. 05000448
1420 SE Roberts Avenue 45° 29′ 10,8″ N , 122° 25′ 0,5″ W 45.486338 -122.416815
Gresham
2
Rae Selling Berry Garden and House
Rae Selling Berry Garden and House weitere Bilder
31. Dez. 2002 ID-Nr. 02001637
11505 SW Summerville Avenue 45° 26′ 32,6″ N , 122° 39′ 42,8″ W 45.44238 -122.6619
Portland
3
Bonneville Dam Historic District
Bonneville Dam Historic District
9. Apr. 1986 ID-Nr. 86000727
Between Interstate 84 and Washington State Route 14 45° 38′ 29″ N , 121° 56′ 40,6″ W 45.64138 -121.9446
Bonneville (and North Bonneville, Washington )
Erbaut in den 1930, Dammbauwerk mit hydroelectrischen Kraftwerk, Leistung: 500.000 kW .
4
Bybee–Howell House
Bybee–Howell House weitere Bilder
5. Nov. 1974 ID-Nr. 74001716
13901 NW Howell Park Road 45° 38′ 29″ N , 122° 49′ 7,9″ W 45.641375 -122.818872
Sauvie Island
5
Columbia River Highway Historic District
Columbia River Highway Historic District weitere Bilder
12. Dez. 1983 ID-Nr. 83004168
Straße entlang des Columbia River 45° 32′ 23,1″ N , 122° 14′ 38,8″ W 45.539747 -122.244119
Troutdale bis The Dalles
Erbaut zwischen 1913 and 1922, vor allem zur Förderung des Tourismus für den Columbia River Gorge
6
Elliott R. Corbett House
Elliott R. Corbett House
3. Okt. 1996 ID-Nr. 96001070
01600 SW Greenwood Road 45° 26′ 1,2″ N , 122° 39′ 43,5″ W 45.433669 -122.662073
Portland (Umgebung)
Erbaut 1915, Baustil: Colonial Revival , Wohnhaus nach dem Entwurf von Whitehouse and Fouilhoux [2]
7
H. L. and Gretchen Hoyt Corbett House
H. L. and Gretchen Hoyt Corbett House
28. Feb. 1991 ID-Nr. 91000129
01405 SW Corbett Hill Circle 45° 26′ 18,8″ N , 122° 39′ 50,4″ W 45.438562 -122.663987
Portland
8
Maurice Crumpacker House
Maurice Crumpacker House weitere Bilder
23. Okt. 1992 ID-Nr. 92001378
12714 SW Iron Mountain Boulevard 45° 25′ 58,9″ N , 122° 39′ 30,1″ W 45.433017 -122.65837
Portland (Umgebung)
9
Fairview City Jail
Fairview City Jail
23. Mai 2016 ID-Nr. 16000290
120 1st Street 45° 32′ 21,8″ N , 122° 26′ 1,4″ W 45.539395 -122.433726
Fairview
10
Roy and Leola Gangware House
Roy and Leola Gangware House
23. Feb. 1990 ID-Nr. 90000284
4848 SW Humphrey Boulevard 45° 30′ 16,5″ N , 122° 43′ 35,1″ W 45.504596 -122.726419
Portland
11
William Gedamke House
William Gedamke House
13. Nov. 1989 ID-Nr. 89001970
1304 E Powell Boulevard 45° 29′ 51,6″ N , 122° 25′ 6,4″ W 45.497678 -122.418444
Gresham
Erbaut ca. 1900, Baustil Queen-Anne-Stil
12
Andreas Graf House
Andreas Graf House
13. Nov. 1980 ID-Nr. 80003356
44222 SE Loudon Road 45° 30′ 39,7″ N , 122° 12′ 29,3″ W 45.511019 -122.208151
Corbett
Erbaut 1985, Baustil ursprünglich Carpenter Gothic , 1891 umgestaltet zum Queen-Anne-Stil .
13
Gresham Carnegie Library
Gresham Carnegie Library weitere Bilder
24. Jan. 2000 ID-Nr. 99001715
410 N Main Street 45° 30′ 1,9″ N , 122° 25′ 50,6″ W 45.500532 -122.430715
Gresham
14
Charles Hunter Hamlin House
Charles Hunter Hamlin House
7. Juni 2016 ID-Nr. 16000346
1322 SE 282nd Avenue 45° 29′ 12,9″ N , 122° 22′ 20,3″ W 45.486909 -122.372295
Gresham
15
Fred Harlow House
Fred Harlow House
16. Feb. 1984 ID-Nr. 84003078
726 E Historic Columbia River Highway 45° 32′ 17,3″ N , 122° 22′ 57,1″ W 45.53815 -122.382532
Troutdale
16
Pierre Rossiter and Charlotte Hines House
Pierre Rossiter and Charlotte Hines House
20. Juni 2002 ID-Nr. 02000660
02393 SW Military Road 45° 26′ 33,7″ N , 122° 39′ 17,5″ W 45.442694 -122.654858
Portland
17
Dr. Herbert H. Hughes House
Dr. Herbert H. Hughes House
5. Sep. 2001 ID-Nr. 01000932
1229 W Powell Boulevard 45° 29′ 50,7″ N , 122° 26′ 40,4″ W 45.497403 -122.444565
Gresham
18
Joseph Jacobberger Country House
Joseph Jacobberger Country House weitere Bilder
24. Jan. 2011 ID-Nr. 10001171
5545 SW Sweetbriar Street 45° 29′ 56″ N , 122° 44′ 4″ W 45.498889 -122.734444
Portland
Erbaut 1916, Architekt: Joseph Jacobberger (1869–1930)
19
C. Hunt and Gertrude McClintock Lewis House
C. Hunt and Gertrude McClintock Lewis House
3. März 2015 ID-Nr. 15000054
11645 SW Military Lane 45° 26′ 26,8″ N , 122° 39′ 12,3″ W 45.440781 -122.653405
Portland
20
Louise Home Hospital and Residence Hall
Louise Home Hospital and Residence Hall
10. Sep. 1987 ID-Nr. 87001556
722 NE 162nd Avenue 45° 31′ 41,5″ N , 122° 29′ 44,6″ W 45.528186 -122.495725
Gresham
21
Donald and Ruth McGraw House
Donald and Ruth McGraw House
3. Sep. 2001 ID-Nr. 01000935
01845 SW Military Road 45° 26′ 22,4″ N , 122° 39′ 35″ W 45.439555 -122.659709
Portland
22
Multnomah County Poor Farm
Multnomah County Poor Farm weitere Bilder
1. Juni 1990 ID-Nr. 90000844
2126 SW Halsey Street 45° 32′ 13,2″ N , 122° 24′ 24,4″ W 45.537005 -122.406784
Troutdale
23
Multnomah Falls Lodge and Footpath
Multnomah Falls Lodge and Footpath weitere Bilder
22. Apr. 1981 ID-Nr. 81000512
Historic Columbia River Highway , nordöstlich von Bridal Veil 45° 34′ 38,1″ N , 122° 7′ 2″ W 45.577247 -122.117218
Bridal Veil (Umgebung)
24
E. J. O'Donnell House
E. J. O'Donnell House
28. Jan. 1994 ID-Nr. 93001564
5535 SW Hewett Boulevard 45° 30′ 16″ N , 122° 44′ 3,7″ W 45.504446 -122.734352
Portland
25
Charles and Fae Olson House
Charles and Fae Olson House weitere Bilder
7. Sep. 2007 ID-Nr. 07000921
765 SW Walters Road 45° 29′ 29,7″ N , 122° 26′ 1,6″ W 45.491587 -122.433768
Gresham
26
David and Marianne Ott House
David and Marianne Ott House
20. Apr. 2015 ID-Nr. 15000167
2075 SE Palmblad Road 45° 28′ 56,8″ N , 122° 24′ 14,2″ W 45.482434 -122.403952
Gresham
27
John V. G. Posey House
John V. G. Posey House
17. Okt. 1990 ID-Nr. 90001517
02107 SW Greenwood Road 45° 26′ 11,4″ N , 122° 39′ 26,4″ W 45.436487 -122.657336
Portland
28
Dr. A. E. and Phila Jane Rockey House
Dr. A. E. and Phila Jane Rockey House weitere Bilder
2. Dez. 1985 ID-Nr. 85003036
10263 SW Riverside Drive 45° 27′ 2,6″ N , 122° 39′ 37,4″ W 45.45073 -122.660399
Portland
29
Percy A. Smith House
Percy A. Smith House
22. Feb. 1991 ID-Nr. 91000135
01837 SW Greenwood Road 45° 26′ 10,9″ N , 122° 39′ 37,6″ W 45.436369 -122.660433
Portland
30
Stanley C. E. Smith House
Stanley C. E. Smith House
19. Juni 1991 ID-Nr. 91000796
01905 SW Greenwood Road 45° 26′ 11,2″ N , 122° 39′ 30,5″ W 45.436441 -122.65848
Portland (Umgebung)
31
Springdale School
Springdale School weitere Bilder
25. Okt. 2011 ID-Nr. 11000771
32405 E Historic Columbia River Highway 45° 31′ 9,8″ N , 122° 19′ 46,5″ W 45.51939 -122.32958
Corbett (Umgebung)
32
Sunken Village Archeological Site (35MU4)
Sunken Village Archeological Site (35MU4)
20. Dez. 1989 ID-Nr. 89002455
(geheim) Koordinaten fehlen
Sauvie Island
Archäologische Stätte, einstmals ein Dorf der Chinookan
33
Troutdale Methodist Episcopal Church
Troutdale Methodist Episcopal Church
9. Sep. 1993 ID-Nr. 93000921
302 SE Harlow Street 45° 32′ 21″ N , 122° 23′ 10,2″ W 45.53918 -122.386155
Troutdale
34
View Point Inn
View Point Inn weitere Bilder
28. Feb. 1985 ID-Nr. 85000367
40301 NE Larch Mountain Road 45° 31′ 58,6″ N , 122° 14′ 54,5″ W 45.532949 -122.248482
Corbett
Architekt: Carl L. Linde
35
Vista House
Vista House weitere Bilder
5. Nov. 1974 ID-Nr. 74001705
Historic Columbia River Highway 45° 32′ 22,5″ N , 122° 14′ 39,8″ W 45.539579 -122.244401
Crown Point
36
Whidden–Kerr House and Garden
Whidden–Kerr House and Garden
13. Okt. 1988 ID-Nr. 88001039
11648 SW Military Lane 45° 26′ 29,2″ N , 122° 39′ 7,8″ W 45.441435 -122.652169
Portland
Erbaut 1901, Architekt: William M. Whidden , Baustil: Prairie School
37
Theodore B. Wilcox Country Estate
Theodore B. Wilcox Country Estate
19. Feb. 1993 ID-Nr. 93000019
3707 SW 52nd Place 45° 29′ 46,5″ N , 122° 43′ 46,3″ W 45.496238 -122.729535
Portland
38
Jacob Zimmerman House
Jacob Zimmerman House
5. Juni 1986 ID-Nr. 86001226
17111 NE Sandy Boulevard 45° 32′ 55″ N , 122° 29′ 13,9″ W 45.548621 -122.487182
Gresham