Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lee County (Alabama)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Registered Historic Places im Lee County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Lee County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Aktuelle Einträge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lfd. Nr. Name Bild Datum der Eintragung Adresse/Lage Ort ID-Nr. Beschreibung
1 Auburn Players Theater 22. Mai 1973 College Ave. at Thach St. Auburn 73000351
2 Auburn University Historic District 3. Juni 1976 Auburn University campus Auburn 76000338
3 Cullars Rotation 18. Apr. 2003 Woodfield Dr., E of US 29 Auburn 03000231
4 Dr. Andrew D. McLain Office and Drug Store 3. Feb. 1983 Main and Crawford Sts. Salem 83002978
5 Dr. J. W. Darden House 12. Aug. 2009 1323 Auburn St. Opelika 09000605
6 Ebenezer Missionary Baptist Church 21. Apr. 1975 Thach St. and Auburn Dr. S Auburn 75000317
7 Franklin Yarbrough Jr. Store 29. Juni 1989 Co. Hwy. 68 Beaulah 89000309
8 Geneva Street Historic District 15. Sep. 1987 Roughly bounded by S. Seventh, Glenn, Stowe, Geneva, and S. Tenth Sts., and Ave. C Opelika 87000981
9 Jenkins Farmhouse 15. Jan. 2008 1190 Co. Rd. 38 Dupree 07001390
10 Lee County Courthouse 23. Juli 1973 S. 9th St. between Aves. A and B Opelika 73000353
11 Loachapoka Historic District 11. Mai 1973 Both sides of AL 14 in Loachapoka Loachapoka 73000352 Auch bekannt als Ruth Purdy Speake Historic Site
12 Lowther House Complex 16. Sep. 1993 Lee Co. Rd. 318 Smiths Station 93000986
13 Noble Hall 24. März 1972 3 mi. N of Auburn on Shelton Mill Rd. Auburn 72000163 Auch bekannt als Frazer-Brown-Pearson Home
14 Northside Historic District 31. Dez. 2001 Roughly Bounded by 7th Ave., 3rd St., 2nd Ave., and N. 11th St. Opelika 01001409
15 Old Main and Church Street Historic District 19. Okt. 1978 Roughly bounded by E. Drake Ave., Western RR of Alabama, N. Gay St., N. College St. and Bragg Ave. and Warrior Ct. Auburn 78003194
16 Old President’s Mansion 29. Aug. 2003 277 W. Thach Ave., Auburn University Auburn 03000423 Auch bekannt als Katharine Cooper Cater Hall
17 Old Rotation 14. Jan. 1988 Auburn University Auburn 87002390
18 Railroad Avenue Historic District 30. Aug. 1984 Roughly bounded by 7th and 10th Sts., 1st Ave. and Ave. B Opelika 84000640
19 Robert Wilton Burton House 8. Mai 1980 315 E. Magnolia St. Auburn 80000701
20 Scott-Yarbrough House 16. Apr. 1975 101 DeBardeleben St. Auburn 75000318 Auch bekannt als Pebble Hill
21 Spring Villa 3. Jan. 1978 6 mi. (9,6 km) SE of Opelika on Spring Villa Rd. Opelika 78000494
22 Summers Plantation 21. Feb. 1991 475 Lee Rd. 181 Opelika 91000095
23 Sunny Slope 12. März 2009 1031 S. College St. Auburn 08001116
24 Auburn City Hall 21. Juni 1983 144 Tichenor Ave. Auburn 83002979
25 U.S. Post Office 18. Nov. 1976 701 Ave. A Opelika 76000339 Auch bekannt als George W. Andrews Federal Building

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]