Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Einträge im National Register of Historic Places in New Bedford (Massachusetts)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Lage des Bristol County in Massachusetts

Die Liste der Einträge im National Register of Historic Places in New Bedford in Massachusetts führt alle Bauwerke, National Historic Landmarks und historischen Stätten in New Bedford auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Die vorliegende Liste wurde aufgrund der Vielzahl an Einträgen in New Bedford ausgelagert und ist integraler Bestandteil der Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Bristol County.[1]

Legende[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

NRHP Historic Place
NHL Historic Landmark
NHLD Historic Landmark District
HD Historic District

Aktuelle Einträge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

[2] Name[3] Bild Eintragsdatum Lage Ort Beschreibung
1 Acushnet Heights Historic District
Acushnet Heights Historic District
Acushnet Heights Historic District
1. Dez. 1989
ID-Nr. 89002035

41° 38′ 52″ N, 70° 55′ 53″ W
New Bedford
2 Butler Flats Light
Butler Flats Light
Butler Flats Light
15. Juni 1987
ID-Nr. 87001530
New Bedford Channel
41° 36′ 7″ N, 70° 53′ 54″ W
New Bedford
3 Buttonwood Park Historic District
Buttonwood Park Historic District
Buttonwood Park Historic District
24. Aug. 2000
ID-Nr. 00000915
Kempton St., Rockdale Ave., Hawthorne St. und Brownell Ave.
41° 37′ 55″ N, 70° 57′ 7″ W
New Bedford
4 Sgt. William H. Carney House
Sgt. William H. Carney House
Sgt. William H. Carney House
21. Apr. 1975
ID-Nr. 75000243
128 Mill St.
41° 38′ 15″ N, 70° 55′ 59″ W
New Bedford
5 Central New Bedford Historic District
Central New Bedford Historic District
Central New Bedford Historic District

weitere Bilder
24. Apr. 1980
ID-Nr. 80000430

41° 38′ 6″ N, 70° 55′ 39″ W
New Bedford
6 County Street Historic District
County Street Historic District
County Street Historic District
11. Aug. 1976
ID-Nr. 76000229

41° 37′ 55″ N, 70° 55′ 55″ W
New Bedford
7 Dawson Building
Dawson Building
Dawson Building
30. Sep. 1982
ID-Nr. 82001900
1851 Purchase St.
41° 39′ 0″ N, 70° 55′ 48″ W
New Bedford
8 Thomas Donaghy School
Thomas Donaghy School
Thomas Donaghy School
2. März 1989
ID-Nr. 89000041
68 South St.
41° 37′ 33″ N, 70° 55′ 25″ W
New Bedford
9 Ernestina (schooner)
Ernestina (schooner)
Ernestina (schooner)

weitere Bilder
3. Jan. 1985
ID-Nr. 85000022
Steamship Wharf
41° 38′ 1″ N, 70° 55′ 16″ W
New Bedford
10 Fire Station No. 4
Fire Station No. 4
Fire Station No. 4
24. Juli 1975
ID-Nr. 75000250
79 S. 6th St.
41° 37′ 41″ N, 70° 55′ 38″ W
New Bedford Heute Standort des New Bedford Fire Museum.
11 First Baptist Church
First Baptist Church
First Baptist Church
21. Apr. 1975
ID-Nr. 75000251
149 William St.
41° 38′ 6″ N, 70° 55′ 44″ W
New Bedford
12 Fort Taber District
Fort Taber District
Fort Taber District
8. Feb. 1973
ID-Nr. 73001954

41° 35′ 36″ N, 70° 54′ 14″ W
New Bedford
13 Griffin Street Cemetery
Griffin Street Cemetery
Griffin Street Cemetery
19. März 2014
ID-Nr. 14000062
S. 2nd & Griffin Sts.
41° 37′ 42″ N, 70° 55′ 21,9″ W
New Bedford
14 Hazelwood Park
Hazelwood Park
Hazelwood Park
24. Juni 2010
ID-Nr. 10000389
597-603 Brock Ave.
41° 36′ 24″ N, 70° 54′ 48″ W
New Bedford
15 Head of the River Historic District
Head of the River Historic District
Head of the River Historic District
2. Dez. 2009
ID-Nr. 09000965
2-28 Mill Rd., 2-13 Tarkiln Hill Rd.
41° 40′ 54,2″ N, 70° 55′ 9,1″ W
New Bedford Erstreckt sich bis auf das Stadtgebiet von Acushnet.
16 Hotel Waverly
Hotel Waverly
Hotel Waverly
26. Jan. 1990
ID-Nr. 89002326
1162-1166 Acushnet Ave.
41° 39′ 26″ N, 70° 55′ 38″ W
New Bedford
17 Howland Mill Village Historic District
Howland Mill Village Historic District
Howland Mill Village Historic District
30. Mai 1996
ID-Nr. 96000609

41° 36′ 58″ N, 70° 56′ 0″ W
New Bedford
18 Robert C. Ingraham School
Robert C. Ingraham School
Robert C. Ingraham School
2. März 2010
ID-Nr. 10000056
80 Rivet St.
41° 37′ 14,2″ N, 70° 55′ 20,3″ W
New Bedford
19 Jewish Cemetery
Jewish Cemetery
Jewish Cemetery
15. Apr. 2014
ID-Nr. 14000155
Old Plainville Road
41° 40′ 50,9″ N, 70° 58′ 1,2″ W
New Bedford
20 Nathan and Mary Johnson Properties
Nathan and Mary Johnson Properties
Nathan and Mary Johnson Properties
16. Feb. 2000
ID-Nr. 00000260

41° 37′ 59″ N, 70° 55′ 44″ W
New Bedford Standort der Underground Railroad
21 Lightship No. 114 30. Mai 1990
ID-Nr. 90000777

41° 38′ 8″ N, 70° 55′ 16″ W
New Bedford Im Mai 2007 verschrottet.
22 Manomet Mills
Manomet Mills
Manomet Mills
24. Mai 2012
ID-Nr. 12000304
194-194R, 200 Riverside Ave.
41° 40′ 3″ N, 70° 55′ 12,1″ W
New Bedford
23 Merrill’s Wharf Historic District
Merrill’s Wharf Historic District
Merrill’s Wharf Historic District
11. Nov. 1977
ID-Nr. 77000167
MacArthur Dr.
41° 37′ 59″ N, 70° 55′ 15″ W
New Bedford
24 Moreland Terrace Historic District
Moreland Terrace Historic District
Moreland Terrace Historic District
3. Juni 1996
ID-Nr. 96000610

41° 37′ 40″ N, 70° 56′ 11″ W
New Bedford
25 New Bedford Gas and Edison Light Complex
New Bedford Gas and Edison Light Complex
New Bedford Gas and Edison Light Complex
3. Juni 2002
ID-Nr. 02000633
180 MacArthur Dr.
41° 37′ 49″ N, 70° 55′ 16″ W
New Bedford
26 New Bedford Historic District
New Bedford Historic District
New Bedford Historic District

weitere Bilder
13. Nov. 1966
ID-Nr. 66000773

41° 38′ 7″ N, 70° 55′ 27″ W
New Bedford
27 New Bedford Whaling National Historical Park
New Bedford Whaling National Historical Park
New Bedford Whaling National Historical Park
12. Nov. 1996
ID-Nr. 03000283
33 William St.
41° 38′ 8,5″ N, 70° 55′ 26,6″ W
New Bedford
28 North Bedford Historic District
North Bedford Historic District
North Bedford Historic District
19. Sep. 1979
ID-Nr. 00000899

41° 38′ 25″ N, 70° 55′ 49″ W
New Bedford
29 Oak Grove Cemetery
Oak Grove Cemetery
Oak Grove Cemetery
28. Apr. 2014
ID-Nr. 14000176
Parker St.
41° 38′ 37,3″ N, 70° 56′ 31,9″ W
New Bedford
30 Old Third District Courthouse
Old Third District Courthouse
Old Third District Courthouse
28. Sep. 1971
ID-Nr. 71000083
2nd und William Sts.
41° 38′ 9″ N, 70° 55′ 29″ W
New Bedford
31 Palmer Island Light Station
Palmer Island Light Station
Palmer Island Light Station
26. März 1980
ID-Nr. 80000433
New Bedford Harbor
41° 37′ 34″ N, 70° 54′ 35″ W
New Bedford
32 William J. Rotch Gothic Cottage
William J. Rotch Gothic Cottage
William J. Rotch Gothic Cottage

weitere Bilder
17. Feb. 2006
ID-Nr. 06000236
19 Irving St.
41° 37′ 49,8″ N, 70° 55′ 54,5″ W
New Bedford
33 William Rotch, Jr. House
William Rotch, Jr. House
William Rotch, Jr. House

weitere Bilder
5. Apr. 2005
ID-Nr. 05000456
396 County Street
41° 37′ 49,1″ N, 70° 55′ 43,3″ W
New Bedford
34 Rural Cemetery and Friends Cemetery
Rural Cemetery and Friends Cemetery
Rural Cemetery and Friends Cemetery
28. Apr. 2014
ID-Nr. 14000177
149 Dartmouth St.
41° 37′ 22,4″ N, 70° 56′ 7,4″ W
New Bedford
35 Shawmut Diner
Shawmut Diner
Shawmut Diner
28. Nov. 2003
ID-Nr. 03001208
943 Shawmut Ave.
41° 39′ 32″ N, 70° 56′ 51″ W
New Bedford
36 Bradford Smith Building 17. Mai 1984
ID-Nr. 84002216
1927-1941 Purchase St.
41° 39′ 4″ N, 70° 55′ 49″ W
New Bedford Nicht mehr existent.
37 Thompson Street School
Thompson Street School
Thompson Street School
26. Jan. 1990
ID-Nr. 89002329
58 Crapo St.
41° 37′ 17″ N, 70° 55′ 37″ W
New Bedford
38 Times and Olympia Buildings
Times and Olympia Buildings
Times and Olympia Buildings
7. Juli 1983
ID-Nr. 83000725
908-912 und 880-898 Purchase St.
41° 38′ 11″ N, 70° 55′ 36″ W
New Bedford
39 U.S. Customhouse
U.S. Customhouse
U.S. Customhouse

weitere Bilder
30. Dez. 1970
ID-Nr. 70000735

41° 38′ 7″ N, 70° 55′ 29″ W
New Bedford
40 Union Baptist Church
Union Baptist Church
Union Baptist Church
16. Juni 2008
ID-Nr. 08000532
109 Court St.
41° 38′ 3,1″ N, 70° 56′ 5,2″ W
New Bedford
41 Union Street Railway Carbarn, Repair Shop
Union Street Railway Carbarn, Repair Shop
Union Street Railway Carbarn, Repair Shop
2. Okt. 1978
ID-Nr. 78000431
1959 Purchase St.
41° 39′ 7″ N, 70° 55′ 52″ W
New Bedford
42 Wamsutta Mills
Wamsutta Mills
Wamsutta Mills
19. Aug. 2008
ID-Nr. 08000794
Acushnet Ave., Logan, Wamsutta und N. Front St.
41° 39′ 5,3″ N, 70° 55′ 39,5″ W
New Bedford
43 Whitman Mills
Whitman Mills
Whitman Mills
29. Aug. 2003
ID-Nr. 03000844

41° 39′ 45″ N, 70° 55′ 10″ W
New Bedford

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Commons: National Register of Historic Places in New Bedford, Massachusetts – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Auszug aus dem National Register of Historic Places - Bristol County Abgerufen am 27. Dezember 2015
  2. Die Nummerierung in dieser Listenspalte ist an der vom National Park Service vorgelegten Reihenfolge der Einträge orientiert; die Farben unterscheiden verschiedene Schutzgebietstypen des Nationalparksystems mit landesweiter Bedeutung (z. B. National Historic Landmarks) von den sonstigen Einträgen im National Register of Historic Places.
  3. National Register Information System. In: National Register of Historic Places. National Park Service, abgerufen am 24. April 2008 (englisch).